Ny sökning
1-20 av 835
Ej tillgängligt eftersom du har aktiverat plats-, datum- eller bildfilter
  1. Registerinformation.
    Namn
    Tim Sovee
    Övrigt
    23 Jul 1985 (23 juli 1985) USA, Guam and Marshall Islands
  2. Registerinformation.
    Namn
    Tim Sovee
    Övrigt
    24 Jul 1985 (24 juli 1985) USA, Guam and Marshall Islands
  3. Registerinformation.
    Namn
    Tim Sovee
    Övrigt
    26 Jul 1985 (26 juli 1985) USA, Guam and Marshall Islands
  4. Registerinformation.
    Namn
    Tim Sovee
    Övrigt
    29 Jul 1985 (29 juli 1985) USA, Guam and Marshall Islands
  5. Registerinformation.
    Namn
    Mrs Sove
  6. Registerinformation.
    Namn
    Mr Horatio Lloyd,-sove
    Bostadsort
    4 Jun 1881 (4 juni 1881) Bangor, Gwynedd, Wales
  7. Registerinformation.
    Namn
    Miss Sove
    Bostadsort
    14 May 1894 (14 maj 1894) Cardiff, South Glamorgan, Wales
  8. Registerinformation.
    Namn
    M Sgt George E Sovie
    Övrigt
    30 Sep 1958 (30 sep. 1958) USA, Guam and Marshall Islands
  9. Registerinformation.
    Namn
    M Sgt George E Sovie
    Övrigt
    20 Oct 1958 (20 okt. 1958) USA, Guam and Marshall Islands
  10. Registerinformation.
    Namn
    M Sgt George E Sovie
    Övrigt
    21 Oct 1958 (21 okt. 1958) USA, Guam and Marshall Islands
  11. Registerinformation.
    Namn
    M Sgt George E Sovie
    Övrigt
    21 Oct 1958 (21 okt. 1958) USA, Guam and Marshall Islands
  12. Australia, Victoria, Government Gazettes, 1851-1907
    Tidskrifter och magasin
    Registerinformation.
    Namn
    E Sofe
    Bostadsort
    10 Jun. 1862 (10 juni 1862) Amherst, Victoria, Australia (Australien)
  13. Australien, lutheranska publikationer, 1913-1966
    Tidskrifter och magasin
    Registerinformation.
    Namn
    Miss Sophie
  14. Australia, Victoria, Government Gazettes, 1851-1907
    Tidskrifter och magasin
    Registerinformation.
    Namn
    Ebenezer Sofe
    Bostadsort
    5 Apr. 1865 Amherst, Victoria, Australia (Australien)
  15. Australien, lutheranska publikationer, 1913-1966
    Tidskrifter och magasin
    Registerinformation.
    Namn
    Ottilie Johanne Sophie
  16. Registerinformation.
    Namn
    Little Soph
  17. Registerinformation.
    Namn
    Alley Save
    Bostadsort
    1896 Windorah
  18. Registerinformation.
    Namn
    Little Soph
  19. Registerinformation.
    Namn
    C. L. Suve
    Bostadsort
    1901 Manor Street
  20. Australia, Victoria, Government Gazettes, 1851-1907
    Tidskrifter och magasin
    Registerinformation.
    Namn
    Frederick Soffe
    Bostadsort
    21 Oct. 1870 (21 okt. 1870) Deptford, Victoria, Australia (Australien)
  1. Övrigt
    23 Jul 1985 (23 juli 1985)
    USA, Guam and Marshall Islands
  2. Övrigt
    24 Jul 1985 (24 juli 1985)
    USA, Guam and Marshall Islands
  3. Övrigt
    26 Jul 1985 (26 juli 1985)
    USA, Guam and Marshall Islands
  4. Övrigt
    29 Jul 1985 (29 juli 1985)
    USA, Guam and Marshall Islands
  5. Bostadsort
    14 May 1894 (14 maj 1894)
    Cardiff, South Glamorgan, Wales
  6. Övrigt
    30 Sep 1958 (30 sep. 1958)
    USA, Guam and Marshall Islands
  7. Övrigt
    20 Oct 1958 (20 okt. 1958)
    USA, Guam and Marshall Islands
  8. Övrigt
    21 Oct 1958 (21 okt. 1958)
    USA, Guam and Marshall Islands
  9. Övrigt
    21 Oct 1958 (21 okt. 1958)
    USA, Guam and Marshall Islands
  10. Bostadsort
    10 Jun. 1862 (10 juni 1862)
    Amherst, Victoria, Australia (Australien)
  11. Bostadsort
    5 Apr. 1865
    Amherst, Victoria, Australia (Australien)
  12. Bostadsort
    21 Oct. 1870 (21 okt. 1870)
    Deptford, Victoria, Australia (Australien)
1-20 av 835 resultat
per sida

Kortkommandon

  • Alt + nNy
  • Alt + rFörfina
  • Alt + pFörhandsvisa dokument
  • Alt + ]Nästa resultat
  • Alt + [Tidigare resultat